-
V7 INTERNATIONAL LIMITED - Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road, Whitefield, Greater Manchester, M45 7TA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07762230
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road
- Whitefield
- Greater Manchester
- M45 7TA Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road, Whitefield, Greater Manchester, M45 7TA UK
Management
- Geschäftsführung
- DRUMMOND JONES, Keith
- WHISTON, Steven Ian
- Prokuristen
- DRUMMOND JONES, Anita
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.09.2011
- Alter der Firma 2011-09-05 12 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Keith Drummond Jones
- Mrs Anita Drummond Jones
- Mr Steven Ian Whiston
- Mr Keith Drummond Jones
- Mrs Anita Drummond Jones
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- VELOCITY GROUP LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-24
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-10-17
- Letzte Einreichung: 2019-09-05
-
V7 INTERNATIONAL LIMITED Firmenbeschreibung
- V7 INTERNATIONAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07762230. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.09.2011 registriert. V7 INTERNATIONAL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VELOCITY GROUP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road erreicht werden.
Jetzt sichern V7 INTERNATIONAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: V7 International Limited - Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road, Whitefield, Greater Manchester, M45 7TA, Grossbritannien
- 2011-09-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu V7 INTERNATIONAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
resolution (2020-09-28) - RESOLUTIONS
-
gazette-notice-compulsory (2020-02-25) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-03-14) - DISS16(SOAS)
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-09-25) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-25) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-09-22) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-24) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-19) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-19) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-09-19) - PSC04
-
resolution (2018-09-24) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-26) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-10-11) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-30) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-29) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-23) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-03-14) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-19) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-01-03) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-01-03) - AP03
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-12-17) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-05) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-06-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-01-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-18) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-03-25) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-25) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-03-25) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-03-25) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-11-26) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-11-26) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-09-05) - NEWINC