-
FX FIRE & SAFETY SOLUTIONS LIMITED - 7 Granard Business Centre, Bunns Lane, Mill Hill, London, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07749167
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 7 Granard Business Centre
- Bunns Lane
- Mill Hill
- London
- NW7 2DQ 7 Granard Business Centre, Bunns Lane, Mill Hill, London, NW7 2DQ UK
Management
- Geschäftsführung
- UPAUL, Jaswant Singh
- WHITE, Rowland Spencer
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.08.2011
- Alter der Firma 2011-08-23 12 Jahre
- SIC/NACE
- 46900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- James Charlton Leete
- Mr Jaswant Singh Upaul
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- F X FIRE & SAFETY SOLUTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-06
- Letzte Einreichung: 2020-08-23
-
FX FIRE & SAFETY SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- FX FIRE & SAFETY SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07749167. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.08.2011 registriert. FX FIRE & SAFETY SOLUTIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen F X FIRE & SAFETY SOLUTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 7 Granard Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern FX FIRE & SAFETY SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fx Fire & Safety Solutions Limited - 7 Granard Business Centre, Bunns Lane, Mill Hill, London, Grossbritannien
- 2011-08-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FX FIRE & SAFETY SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-15) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-09) - TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-05-28) - SH03
-
resolution (2019-06-10) - RESOLUTIONS
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-09) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-02) - AP01
-
capital-allotment-shares (2019-07-05) - SH01
-
capital-cancellation-shares (2019-06-10) - SH06
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-24) - CS01
-
resolution (2018-05-08) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2018-04-09) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-04-09) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-24) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-24) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-08) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-13) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-09-10) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-11) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-12) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-13) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-10) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-04-18) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-04-03) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
certificate-change-of-name-company (2011-08-23) - CERTNM
-
incorporation-company (2011-08-23) - NEWINC