-
CLICKETY BOOKS LTD - 20 Bishopston, Montacute, TA15 6UX, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07740716
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 20 Bishopston
- Montacute
- TA15 6UX
- England 20 Bishopston, Montacute, TA15 6UX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- AYRE, Anne Donnison
- AYRE, Richard Malcolm
- Prokuristen
- AYRE, Richard Malcolm
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.08.2011
- Alter der Firma 2011-08-15 12 Jahre
- SIC/NACE
- 18129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard Malcolm Ayre
- Mrs Anne Donnison Ayre
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-05-31
- Letzte Einreichung: 2023-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-29
- Letzte Einreichung: 2023-08-15
-
CLICKETY BOOKS LTD Firmenbeschreibung
- CLICKETY BOOKS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07740716. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.08.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "18129" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 20 Bishopston erreicht werden.
Jetzt sichern CLICKETY BOOKS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Clickety Books Ltd - 20 Bishopston, Montacute, TA15 6UX, England, Grossbritannien
- 2011-08-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CLICKETY BOOKS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2024-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-05-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-05-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-29) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-08-21) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-25) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-05-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-02) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-30) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-05-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-11) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-09-11) - SH01
-
capital-allotment-shares (2013-09-02) - SH01
-
resolution (2013-09-02) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-07-24) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-08-15) - NEWINC