-
OXFORD ST DEVELOPMENTS LTD - 9 Stratfield Park, Elettra Avenue, Waterlooville, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07739363
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9 Stratfield Park
- Elettra Avenue
- Waterlooville
- Hampshire
- PO7 7XN 9 Stratfield Park, Elettra Avenue, Waterlooville, Hampshire, PO7 7XN UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIS, Paul Harding
- HACKETT, Kelvin James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.08.2011
- Alter der Firma 2011-08-12 13 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kelvin James Hackett
- Mr Paul Harding Davis
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-04-30
- Letzte Einreichung: 2023-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-06-30
- Letzte Einreichung: 2024-06-16
-
OXFORD ST DEVELOPMENTS LTD Firmenbeschreibung
- OXFORD ST DEVELOPMENTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07739363. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.08.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 9 Stratfield Park erreicht werden.
Jetzt sichern OXFORD ST DEVELOPMENTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Oxford St Developments Ltd - 9 Stratfield Park, Elettra Avenue, Waterlooville, Hampshire, Grossbritannien
- 2011-08-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OXFORD ST DEVELOPMENTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-07-31) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2024-04-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-02-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-22) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-02) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-18) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-04-27) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-16) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-18) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-06-21) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-26) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-03-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-07) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-01-07) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-12) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-06) - AP01
-
capital-allotment-shares (2012-09-06) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-08-12) - NEWINC