-
HOLT TANNERY LTD - Coopers House 65a Wingletye Lane, Hornchurch, Essex, RM11 3AT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07721338
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Coopers House 65a Wingletye Lane
- Hornchurch
- Essex
- RM11 3AT Coopers House 65a Wingletye Lane, Hornchurch, Essex, RM11 3AT UK
Management
- Geschäftsführung
- FIELDSEND, Richard Michael
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-28 13 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Soriah Child
- Mrs Soriah Child
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- HOLT VILLAGE REGENERATION LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-11-15
- Letzte Einreichung: 2018-11-01
-
HOLT TANNERY LTD Firmenbeschreibung
- HOLT TANNERY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07721338. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.07.2011 registriert. HOLT TANNERY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HOLT VILLAGE REGENERATION LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Coopers House 65A Wingletye Lane erreicht werden.
Jetzt sichern HOLT TANNERY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Holt Tannery Ltd - Coopers House 65a Wingletye Lane, Hornchurch, Essex, RM11 3AT, Grossbritannien
- 2011-07-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HOLT TANNERY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-02-18) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2020-01-21) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-05-02) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-28) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-18) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-06-08) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-07) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-02-13) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2019-01-22) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-06) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-01-23) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-01-24) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-02-07) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-22) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-05-15) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-22) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-03-21) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-21) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-22) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-10) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-04) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-11-04) - AP03
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2014-09-29) - AD02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-13) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2014-05-13) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-09) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-05-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
certificate-change-of-name-company (2013-01-03) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-24) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2013-07-30) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-07-31) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-16) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-07) - AR01
-
change-sail-address-company (2013-11-07) - AD02
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-11-07) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-07) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-07-28) - NEWINC