-
LINC CONSULTING LIMITED - 21a Bore Street, Lichfield, Staffordshire, WS13 6LZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07711631
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 21a Bore Street
- Lichfield
- Staffordshire
- WS13 6LZ 21a Bore Street, Lichfield, Staffordshire, WS13 6LZ UK
Management
- Geschäftsführung
- MARGETTS, Elaine
- Prokuristen
- MARGETTS, Elaine
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.07.2011
- Gelöscht am:
- 2022-01-05
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Elaine Margetts
- Mr Jeffrey Dawson
- -
- Ms Elaine Margetts
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-03
- Letzte Einreichung: 2020-07-20
-
LINC CONSULTING LIMITED Firmenbeschreibung
- LINC CONSULTING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07711631. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.07.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 21A Bore Street erreicht werden.
Jetzt sichern LINC CONSULTING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Linc Consulting Limited - 21a Bore Street, Lichfield, Staffordshire, WS13 6LZ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LINC CONSULTING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-17) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-14) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-02) - AD01
-
resolution (2020-11-11) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-31) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-11-11) - LIQ01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-14) - AA
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-11-11) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-26) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-26) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-08) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-02) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-02) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-04) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-04-12) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-04-12) - CH03
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-14) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-01) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-04) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-11-20) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-19) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2012-11-13) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-07-20) - NEWINC