-
PARSONS SON AND BASLEY (AUCTIONS) LTD - 2/3 Pavilion Buildings, Brighton, East Sussex, BN1 1EE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07709579
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2/3 Pavilion Buildings
- Brighton
- East Sussex
- BN1 1EE 2/3 Pavilion Buildings, Brighton, East Sussex, BN1 1EE UK
Management
- Geschäftsführung
- BRINSMEAD, Keith Graham
- HOLDEN, Geoffrey Philip
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-19 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68310
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Keith Graham Brinsmead
- Mr Geoffrey Philip Holden
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-30
- Letzte Einreichung: 2019-07-19
-
PARSONS SON AND BASLEY (AUCTIONS) LTD Firmenbeschreibung
- PARSONS SON AND BASLEY (AUCTIONS) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07709579. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.07.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68310" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 2/3 Pavilion Buildings erreicht werden.
Jetzt sichern PARSONS SON AND BASLEY (AUCTIONS) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Parsons Son And Basley (Auctions) Ltd - 2/3 Pavilion Buildings, Brighton, East Sussex, BN1 1EE, Grossbritannien
- 2011-07-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PARSONS SON AND BASLEY (AUCTIONS) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-11-03) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-10-29) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-10-29) - 600
-
resolution (2019-10-29) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-07-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-01-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-31) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-25) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-30) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-01-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-05) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-07-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-12-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-05) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-09-04) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-19) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-08-10) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2011-08-01) - TM01
-
incorporation-company (2011-07-19) - NEWINC