-
AMPHORA MIDCO LIMITED - 3, Field Court, London, WC1R 5EF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07705058
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3
- Field Court
- London
- WC1R 5EF 3, Field Court, London, WC1R 5EF UK
Management
- Geschäftsführung
- BAZIL, Peter John
- TEAGAN, Jens Peter
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.07.2011
- Gelöscht am:
- 2019-04-30
- SIC/NACE
- 62020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Amphora Finco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- DE FACTO 1885 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-09-30
- Letzte Einreichung: 2015-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-07-28
- Letzte Einreichung: 2017-07-14
-
AMPHORA MIDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- AMPHORA MIDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07705058. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 14.07.2011 registriert. AMPHORA MIDCO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DE FACTO 1885 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62020" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2015 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 3 erreicht werden.
Jetzt sichern AMPHORA MIDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Amphora Midco Limited - 3, Field Court, London, WC1R 5EF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AMPHORA MIDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-11-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-19) - CS01
-
resolution (2017-09-28) - RESOLUTIONS
-
legacy (2017-09-28) - CAP-SS
-
legacy (2017-09-28) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2017-09-28) - SH19
-
capital-allotment-shares (2017-11-10) - SH01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-10-18) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2017-10-18) - LIQ01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-20) - AD01
-
resolution (2017-10-18) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-05-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-15) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-10-03) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-05) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-18) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-17) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-28) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-05) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-31) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-24) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-06-23) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-05-19) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-23) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-22) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-05-19) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-09) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2012-05-23) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-05-16) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-08-16) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-08-16) - TM02
-
change-of-name-notice (2011-08-11) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-16) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2011-08-11) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-16) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-08-16) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-30) - AP01
-
resolution (2011-08-30) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2011-08-30) - SH02
-
capital-allotment-shares (2011-08-30) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-08-30) - AP03
-
legacy (2011-08-31) - MG01
-
termination-director-company-with-name (2011-09-07) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-26) - AD01
-
incorporation-company (2011-07-14) - NEWINC