-
POOL HOUSE HOLDINGS LIMITED - Pool House, 30 Dam Street, Lichfield, Staffordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07704205
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Pool House
- 30 Dam Street
- Lichfield
- Staffordshire
- WS13 6AA Pool House, 30 Dam Street, Lichfield, Staffordshire, WS13 6AA UK
Management
- Geschäftsführung
- BURNS, David Robert
- HAIGH, Fiona
- HOVERS, Jonathan Paul
- KALSI, Phoebe
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-13 12 Jahre
- SIC/NACE
- 66290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Robert Burns
- Mrs Rachel Mary Burns
- Mr Jonathan Paul Hovers
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- POOL HOUSE GROUP LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-27
- Letzte Einreichung: 2021-07-13
-
POOL HOUSE HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- POOL HOUSE HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07704205. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.07.2011 registriert. POOL HOUSE HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen POOL HOUSE GROUP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66290" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Pool House erreicht werden.
Jetzt sichern POOL HOUSE HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pool House Holdings Limited - Pool House, 30 Dam Street, Lichfield, Staffordshire, Grossbritannien
- 2011-07-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu POOL HOUSE HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
capital-allotment-shares (2021-02-23) - SH01
-
change-of-name-notice (2021-04-14) - CONNOT
-
resolution (2021-04-14) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-29) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-12-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-12-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-21) - AA
-
memorandum-articles (2020-07-02) - MA
-
resolution (2020-07-02) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-26) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-26) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-26) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-06) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-05-30) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-11) - AA
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2017-04-09) - SH02
-
resolution (2017-06-29) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2017-07-13) - CERTNM
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-17) - CS01
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2017-07-11) - SH02
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-22) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-25) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-16) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-29) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-30) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-31) - AP01
-
resolution (2015-12-31) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-04) - AA
-
capital-allotment-shares (2015-12-31) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-05) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-04-09) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-02) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2012-11-06) - GAZ1
-
capital-allotment-shares (2012-11-07) - SH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-11-07) - DISS40
keyboard_arrow_right 2011
-
certificate-change-of-name-company (2011-09-06) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-09-02) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-02) - AD01
-
incorporation-company (2011-07-13) - NEWINC