-
ADVOCACY BY CONSENT LTD - 6 Shortwheat Hill, Coton Park, Rugby, Warwickshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07691966
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6 Shortwheat Hill
- Coton Park
- Rugby
- Warwickshire
- CV23 0GP 6 Shortwheat Hill, Coton Park, Rugby, Warwickshire, CV23 0GP UK
Management
- Geschäftsführung
- SCOTT, Grant Alexander
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-04 12 Jahre
- SIC/NACE
- 85590
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Grant Alexander Scott
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-29
- Letzte Einreichung: 2022-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-18
- Letzte Einreichung: 2023-07-04
-
ADVOCACY BY CONSENT LTD Firmenbeschreibung
- ADVOCACY BY CONSENT LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07691966. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.07.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85590" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 6 Shortwheat Hill erreicht werden.
Jetzt sichern ADVOCACY BY CONSENT LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Advocacy By Consent Ltd - 6 Shortwheat Hill, Coton Park, Rugby, Warwickshire, Grossbritannien
- 2011-07-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ADVOCACY BY CONSENT LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-notice-voluntary (2024-03-05) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2024-02-25) - DS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-02-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-03-28) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-03-28) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2022-07-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-05-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-05-28) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-05-01) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-04-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-15) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-04-07) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-02-19) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-02-20) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-09-06) - TM01
-
capital-allotment-shares (2013-09-06) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-08-14) - AA
-
capital-allotment-shares (2012-08-08) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-31) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-08-11) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-07-04) - TM01
-
incorporation-company (2011-07-04) - NEWINC