-
INDEPENDENT FINANCIAL MATTERS LTD - 1 Radian Court, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07686881
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Radian Court
- Knowlhill
- Milton Keynes
- MK5 8PJ 1 Radian Court, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PJ UK
Management
- Geschäftsführung
- CONNOLLY, David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-29 13 Jahre
- SIC/NACE
- 64999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Charles Anthony Kleimunt
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- PENSION TRANSFERS (UK) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-12-31
- Letzte Einreichung: 2017-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-06-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-07-12
- Letzte Einreichung: 2017-06-28
-
INDEPENDENT FINANCIAL MATTERS LTD Firmenbeschreibung
- INDEPENDENT FINANCIAL MATTERS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07686881. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.06.2011 registriert. INDEPENDENT FINANCIAL MATTERS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PENSION TRANSFERS (UK) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.06.2013.Die Firma kann schriftlich über 1 Radian Court erreicht werden.
Jetzt sichern INDEPENDENT FINANCIAL MATTERS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Independent Financial Matters Ltd - 1 Radian Court, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PJ, Grossbritannien
- 2011-06-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu INDEPENDENT FINANCIAL MATTERS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2023-03-28) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-03-28) - 600
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-04-24) - 600
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-11-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-11-04) - LIQ03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-20) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-10) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-11-06) - LIQ03
-
liquidation-disclaimer-notice (2019-01-04) - NDISC
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-04) - AD01
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-11-07) - NDISC
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-10-04) - NDISC
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-09-20) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-09-20) - LIQ02
-
resolution (2018-09-20) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-01) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-03-10) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-28) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-06-28) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-03-07) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-09) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-03-11) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-09-27) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-10-11) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-10-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-04-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-02-08) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-02-25) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-02-25) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-08) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-24) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-31) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-06-29) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2011-09-23) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2011-09-09) - CERTNM
-
resolution (2011-08-31) - RESOLUTIONS