-
HAMPSTEAD SLOPE DEVELOPMENTS LIMITED - 341 - 351, Finchley Road, London, NW3 6ET, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07686348
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 341 - 351
- Finchley Road
- London
- NW3 6ET 341 - 351, Finchley Road, London, NW3 6ET UK
Management
- Geschäftsführung
- LEIBOWITZ, Alan Jay
- Prokuristen
- VINER, Nicholas Philip
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-28 12 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nicholas Philip Viner
- -
- Mr Alan Jay Leibovitz
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- GATHERFREE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-10
- Letzte Einreichung: 2023-05-27
-
HAMPSTEAD SLOPE DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- HAMPSTEAD SLOPE DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07686348. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.06.2011 registriert. HAMPSTEAD SLOPE DEVELOPMENTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GATHERFREE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 341 - 351 erreicht werden.
Jetzt sichern HAMPSTEAD SLOPE DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hampstead Slope Developments Limited - 341 - 351, Finchley Road, London, NW3 6ET, Grossbritannien
- 2011-06-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HAMPSTEAD SLOPE DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-02-07) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-06-08) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-22) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-07-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-11-06) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-09) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-10-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-30) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-11-04) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2013-11-18) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-07-10) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-10-07) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-21) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-04) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-04-23) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-02-08) - AA01
-
change-of-name-notice (2012-02-08) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2012-02-08) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-14) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-02-14) - AP03
-
resolution (2012-03-28) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2012-03-28) - MEM/ARTS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-03-28) - AA
-
legacy (2012-06-21) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-12-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-19) - AP01
-
incorporation-company (2011-06-28) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-12-19) - AD01