-
PHP TRADECO LIMITED - 5th Floor Greener House, 66-68 Haymarket, London, SW1Y 4RF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07685933
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5th Floor Greener House
- 66-68 Haymarket
- London
- SW1Y 4RF 5th Floor Greener House, 66-68 Haymarket, London, SW1Y 4RF UK
Management
- Geschäftsführung
- HYMAN, Harry Abraham
- SANTER, Christopher John
- HOWELL, Richard
- Prokuristen
- WRIGHT, Paul Simon Kent
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-28 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Nexus Tradeco Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- NEXUS TRADECO LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-13
- Letzte Einreichung: 2021-06-29
-
PHP TRADECO LIMITED Firmenbeschreibung
- PHP TRADECO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07685933. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.06.2011 registriert. PHP TRADECO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen NEXUS TRADECO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 5Th Floor Greener House erreicht werden.
Jetzt sichern PHP TRADECO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Php Tradeco Limited - 5th Floor Greener House, 66-68 Haymarket, London, SW1Y 4RF, Grossbritannien
- 2011-06-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PHP TRADECO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
resolution (2021-01-06) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-05) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-01-05) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-05) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-01-05) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-01-05) - AA
-
memorandum-articles (2021-01-04) - MA
-
resolution (2021-01-04) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-consolidation (2021-01-14) - SH02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-05) - CS01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2021-07-15) - RP04AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-07-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-29) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-11-10) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-11-09) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-01) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-10) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-10) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-02) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-01) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-19) - PSC02
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-02-11) - SH02
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-12-17) - SH08
-
resolution (2016-12-22) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-10-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-08-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-02-11) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-08) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2013-07-09) - CH04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-09-20) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-12) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-group (2012-07-06) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2012-03-20) - AP04
keyboard_arrow_right 2011
-
resolution (2011-12-19) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2011-12-19) - SH01
-
legacy (2011-12-13) - MG01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-12-19) - AA01
-
incorporation-company (2011-06-28) - NEWINC