-
BEECH JONES LIMITED - DOYLE DAVIES, 6 Ynys Bridge Court, Gwaelod-Y-Garth, Cardiff, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07680654
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- DOYLE DAVIES
- 6 Ynys Bridge Court
- Gwaelod-Y-Garth
- Cardiff
- CF15 9SS
- Wales DOYLE DAVIES, 6 Ynys Bridge Court, Gwaelod-Y-Garth, Cardiff, CF15 9SS, Wales UK
Management
- Geschäftsführung
- GABRIEL, Martin James
- JONES, Barrie Yorath
- Prokuristen
- DUMBLETON, Nicola Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.06.2011
- Gelöscht am:
- 2022-06-26
- SIC/NACE
- 69102
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- BEECH JONES DE LLOYD LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-06-30
- Letzte Einreichung: 2013-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-07-07
- Letzte Einreichung:
-
BEECH JONES LIMITED Firmenbeschreibung
- BEECH JONES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07680654. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.06.2011 registriert. BEECH JONES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BEECH JONES DE LLOYD LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Doyle Davies erreicht werden.
Jetzt sichern BEECH JONES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Beech Jones Limited - DOYLE DAVIES, 6 Ynys Bridge Court, Gwaelod-Y-Garth, Cardiff, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BEECH JONES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-29) - MR04
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-01-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-01-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-01-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-01-20) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-constitution-liquidation-committee (2016-01-07) - 4.48
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-12-16) - 4.20
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-12-15) - 4.68
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-12-14) - 600
-
liquidation-disclaimer-notice (2015-01-28) - F10.2
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-01) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-10-01) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-22) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-18) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-24) - AD01
-
liquidation-resolution-miscellaneous (2014-11-28) - LIQ MISC RES
-
resolution (2014-11-28) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2014-11-28) - 600
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-21) - AR01
-
liquidation-disclaimer-notice (2014-12-30) - F10.2
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2014-11-28) - 4.70
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-02) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2013-08-06) - SH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-22) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-03-22) - AA01
-
capital-cancellation-shares (2013-08-06) - SH06
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-03-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-27) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2012-06-18) - CERTNM
-
legacy (2012-06-28) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-23) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-03) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-22) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-10-24) - AP03
-
certificate-change-of-name-company (2012-12-20) - CERTNM
-
legacy (2012-10-02) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-04) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-09-27) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-11) - AD01
-
resolution (2011-08-05) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2011-06-23) - NEWINC