-
THE BLACK OLIVE (HOUSING) LIMITED - 11, Clifton Moor Business Village, James Nicolson Link, York, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07677871
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11
- Clifton Moor Business Village
- James Nicolson Link
- York
- YO30 4XG 11, Clifton Moor Business Village, James Nicolson Link, York, YO30 4XG UK
Management
- Geschäftsführung
- WATSON, Christopher Paul
- Prokuristen
- WATSON, Christopher Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.06.2011
- Gelöscht am:
- 2020-02-26
- SIC/NACE
- 68209
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- WATSON PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-09-30
- Letzte Einreichung: 2014-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-21
-
THE BLACK OLIVE (HOUSING) LIMITED Firmenbeschreibung
- THE BLACK OLIVE (HOUSING) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07677871. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.06.2011 registriert. THE BLACK OLIVE (HOUSING) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WATSON PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2014 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 11 erreicht werden.
Jetzt sichern THE BLACK OLIVE (HOUSING) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Black Olive (Housing) Limited - 11, Clifton Moor Business Village, James Nicolson Link, York, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE BLACK OLIVE (HOUSING) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-02-26) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-05) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2019-11-26) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-07-12) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-01-09) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2018-07-27) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-01-10) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-05-28) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-06) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-23) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-11-19) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-11-19) - 600
-
resolution (2015-11-19) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-10) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-03-28) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-29) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-09-12) - AA01
-
legacy (2012-11-23) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-12) - AA
-
legacy (2012-11-26) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-08-23) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-08-18) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-08-18) - AA01
-
incorporation-company (2011-06-21) - NEWINC