-
WATERLOO SOLUTIONS LIMITED - 67 Grosvenor Street Mayfair, London, W1K 3JN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07671221
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 67 Grosvenor Street Mayfair
- London
- W1K 3JN 67 Grosvenor Street Mayfair, London, W1K 3JN UK
Management
- Geschäftsführung
- NAFIR, Parminder
- TANDON, Vikas
- Prokuristen
- NAFIR, Parminder
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-15 12 Jahre
- SIC/NACE
- 66190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Vikas Tandon
- Mr Vikas Tandon
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- administration
- Ehemalige Namen
- GKF PARTNERS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-17
- Letzte Einreichung: 2021-06-03
-
WATERLOO SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- WATERLOO SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07671221. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.06.2011 registriert. WATERLOO SOLUTIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GKF PARTNERS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66190" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 67 Grosvenor Street Mayfair erreicht werden.
Jetzt sichern WATERLOO SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Waterloo Solutions Limited - 67 Grosvenor Street Mayfair, London, W1K 3JN, Grossbritannien
- 2011-06-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WATERLOO SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-25) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-07-15) - MR01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2021-10-21) - AM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-10-22) - AD01
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2021-11-30) - AM02
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-24) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-11-13) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-11-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-21) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-18) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-18) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-30) - PSC01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-04-08) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-04-04) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-15) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-29) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-18) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-12-03) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-12-10) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-18) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-18) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-12) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-07) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-03-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-06-29) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-05) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2012-03-26) - TM01
-
appoint-corporate-director-company-with-name (2012-03-26) - AP02
-
certificate-change-of-name-company (2012-04-27) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-08) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-12-07) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2012-04-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
certificate-change-of-name-company (2011-09-07) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-09-07) - CONNOT
-
incorporation-company (2011-06-15) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-15) - AP01