-
POPCHIPS LIMITED - 5th Floor, The Urban Building, 3-9 Albert Street, Slough, SL1 2BE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07656325
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5th Floor, The Urban Building
- 3-9 Albert Street
- Slough
- SL1 2BE
- England 5th Floor, The Urban Building, 3-9 Albert Street, Slough, SL1 2BE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HENDERSON, Giles Alexander Glidden
- RIDDLE, Andrew Steven
- THORPE, Mark Christopher
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-02 13 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Kp Snacks Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-16
- Letzte Einreichung: 2019-06-02
-
POPCHIPS LIMITED Firmenbeschreibung
- POPCHIPS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07656325. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.06.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 5Th Floor, The Urban Building erreicht werden.
Jetzt sichern POPCHIPS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Popchips Limited - 5th Floor, The Urban Building, 3-9 Albert Street, Slough, SL1 2BE, Grossbritannien
- 2011-06-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu POPCHIPS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-04-14) - GAZ1(A)
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-04-01) - MR04
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-04-02) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-10) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-06) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-02-18) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-13) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-20) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-07-20) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-20) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-20) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-15) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-15) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-06-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-14) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-02) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-15) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-02-15) - AP03
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-18) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-02-11) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-13) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-29) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-07-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-03-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-19) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-07-28) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-12-28) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-07-28) - AP03
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-12-24) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-02) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-06) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-03-19) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-02-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-02-04) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-06-02) - NEWINC