-
SWIFT-CUT AUTOMATION LIMITED - 1 Lancaster Park Newborough Road, Needwood, Burton-On-Trent, DE13 9PD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07652903
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Lancaster Park Newborough Road
- Needwood
- Burton-On-Trent
- DE13 9PD
- United Kingdom 1 Lancaster Park Newborough Road, Needwood, Burton-On-Trent, DE13 9PD, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- JEWELL, Curtis Evan
- JOHNSON, Kevin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-31 12 Jahre
- SIC/NACE
- 28990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Charter Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-14
- Letzte Einreichung: 2023-05-31
-
SWIFT-CUT AUTOMATION LIMITED Firmenbeschreibung
- SWIFT-CUT AUTOMATION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07652903. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "28990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 1 Lancaster Park Newborough Road erreicht werden.
Jetzt sichern SWIFT-CUT AUTOMATION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Swift-Cut Automation Limited - 1 Lancaster Park Newborough Road, Needwood, Burton-On-Trent, DE13 9PD, Grossbritannien
- 2011-05-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SWIFT-CUT AUTOMATION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-31) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-05-09) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-05-09) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-06-26) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-05-09) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-12-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-12-19) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-11-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-11-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-30) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-09-28) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-09-28) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-31) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-10) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-14) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-06) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-06) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-19) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date (2015-06-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-27) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-26) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-06-01) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-04) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-11) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-24) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-12-16) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-16) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-09) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-11) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-06-14) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-05-31) - NEWINC