-
SEACROSS PHARMACEUTICALS LTD - Bedford Business Centre, 61-63 St Peters Street, Bedford, Bedfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07650983
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bedford Business Centre
- 61-63 St Peters Street
- Bedford
- Bedfordshire
- MK40 2PR Bedford Business Centre, 61-63 St Peters Street, Bedford, Bedfordshire, MK40 2PR UK
Management
- Geschäftsführung
- DING, Zhao, Dr
- HE, Ping
- Prokuristen
- HE, Ping
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-31 13 Jahre
- SIC/NACE
- 21200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Qianyi Huang
- Mr Zhao Ding
- Mr Qianyi Huang
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-14
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
-
SEACROSS PHARMACEUTICALS LTD Firmenbeschreibung
- SEACROSS PHARMACEUTICALS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07650983. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "21200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Bedford Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern SEACROSS PHARMACEUTICALS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Seacross Pharmaceuticals Ltd - Bedford Business Centre, 61-63 St Peters Street, Bedford, Bedfordshire, Grossbritannien
- 2011-05-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SEACROSS PHARMACEUTICALS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-01) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-21) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-08-16) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-09) - CS01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2018-04-13) - RP04AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-24) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-23) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-04-20) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-07-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-27) - AD01
-
termination-secretary-company (2014-11-24) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-11-24) - AP03
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-10-30) - AP03
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2014-10-28) - MR05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-15) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-10-15) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-12) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-26) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-06-27) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-25) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-22) - AP01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-06-22) - CH03
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-02-29) - AA01
-
legacy (2012-02-24) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-05-31) - NEWINC