-
MEZZA PROPERTIES LIMITED - Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07641324
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Greg's Building
- 1 Booth Street
- Manchester
- M2 4DU Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU UK
Management
- Geschäftsführung
- GORDON, Naomi Clare
- GORDON, Steven Daniel
- JACOBS, Michael Paul
- JACOBS, Samantha Jane
- KESSLER, Amanda
- KESSLER, Daniel Benjamin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-20 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-02-29
- Letzte Einreichung: 2014-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-05-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-06-03
- Letzte Einreichung:
-
MEZZA PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- MEZZA PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07641324. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.05.2015.Die Firma kann schriftlich über Greg's Building erreicht werden.
Jetzt sichern MEZZA PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mezza Properties Limited - Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
- 2011-05-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MEZZA PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-23) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-miscellaneous (2020-07-16) - LIQ MISC
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-09-10) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-09-10) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-09-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-31) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-09-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-09-16) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-25) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-22) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2015-07-21) - 4.70
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-07-21) - 600
-
resolution (2015-07-21) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-17) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-17) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-05-20) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-12) - AP01
-
resolution (2011-07-07) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-13) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-06-07) - SH01