-
7 GLOBAL SYSTEMS LIMITED - Elizabeth House, 13-19 London Road, Newbury, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07617630
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Elizabeth House
- 13-19 London Road
- Newbury
- Berkshire
- RG14 1JL
- United Kingdom Elizabeth House, 13-19 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JL, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- SCHOLEFIELD, Henry Stephen Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.04.2011
- Alter der Firma 2011-04-28 13 Jahre
- SIC/NACE
- 63110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Clarinet Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-12
- Letzte Einreichung: 2024-04-28
-
7 GLOBAL SYSTEMS LIMITED Firmenbeschreibung
- 7 GLOBAL SYSTEMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07617630. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.04.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "63110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Elizabeth House erreicht werden.
Jetzt sichern 7 GLOBAL SYSTEMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 7 Global Systems Limited - Elizabeth House, 13-19 London Road, Newbury, Berkshire, Grossbritannien
- 2011-04-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 7 GLOBAL SYSTEMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-05-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-01-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-24) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-12-21) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-12-20) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-17) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-30) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-21) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-15) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-09-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-26) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-28) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-01) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-07) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-09) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-08) - AR01
-
change-sail-address-company (2013-05-08) - AD02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-07-19) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-19) - AD01
-
incorporation-company (2011-04-28) - NEWINC