-
LANDMARK COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED - 87 Firs Park Avenue, Winchmore Hill, London, N21 2PU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07607768
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 87 Firs Park Avenue
- Winchmore Hill
- London
- N21 2PU
- England 87 Firs Park Avenue, Winchmore Hill, London, N21 2PU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- POLLEDRI, Jon Michael
- POLLEDRI, Michael Anthony
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.04.2011
- Alter der Firma 2011-04-18 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Jon Michael Polledri
- Lee Valley Estates Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-04-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-29
- Letzte Einreichung: 2020-10-15
-
LANDMARK COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- LANDMARK COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07607768. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.04.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.04.2013.Die Firma kann schriftlich über 87 Firs Park Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern LANDMARK COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Landmark Commercial Properties Limited - 87 Firs Park Avenue, Winchmore Hill, London, N21 2PU, Grossbritannien
- 2011-04-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LANDMARK COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-01-26) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-15) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-08) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-09-04) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-15) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-22) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-09-21) - MR04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-15) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-15) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-15) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-15) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-12-04) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-04) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-12-16) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-28) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-24) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-06) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-23) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-06) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-14) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-10) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-04-18) - NEWINC
-
legacy (2011-09-15) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-09) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-05-09) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-19) - TM01
-
capital-allotment-shares (2011-04-21) - SH01