-
VSL INFRASTRUCTURE PROTECTION LIMITED - C/O TENEO RESTRUCTURING LIMITED, 156 Great Charles Street Queensway, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07604404
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O TENEO RESTRUCTURING LIMITED
- 156 Great Charles Street Queensway
- Birmingham
- West Midlands
- B3 3HN C/O TENEO RESTRUCTURING LIMITED, 156 Great Charles Street Queensway, Birmingham, West Midlands, B3 3HN UK
Management
- Geschäftsführung
- MIDENA, Jean-Luc Gustave Marcel
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.04.2011
- Gelöscht am:
- 2022-02-19
- SIC/NACE
- 43290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Vsl International Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-02
- Letzte Einreichung: 2021-06-18
-
VSL INFRASTRUCTURE PROTECTION LIMITED Firmenbeschreibung
- VSL INFRASTRUCTURE PROTECTION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07604404. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 14.04.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43290" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.04.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Teneo Restructuring Limited erreicht werden.
Jetzt sichern VSL INFRASTRUCTURE PROTECTION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vsl Infrastructure Protection Limited - C/O TENEO RESTRUCTURING LIMITED, 156 Great Charles Street Queensway, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VSL INFRASTRUCTURE PROTECTION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2021-11-19) - LIQ13
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-29) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-09-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-17) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-12-10) - 600
-
resolution (2020-12-10) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-12-10) - LIQ01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-10-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-13) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-06-13) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-30) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-13) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-05-22) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-05-22) - CH03
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-11) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-07-29) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-10-03) - AA
-
auditors-resignation-company (2014-08-06) - AUD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-22) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-05-12) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-10-16) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-10-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-06) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-05-06) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2011-05-06) - TM01
-
incorporation-company (2011-04-14) - NEWINC
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-05-06) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-06) - AD01
-
memorandum-articles (2011-07-22) - MEM/ARTS
-
termination-director-company-with-name (2011-05-10) - TM01
-
resolution (2011-07-22) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2011-07-22) - SH01
-
statement-of-companys-objects (2011-07-22) - CC04
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-05-06) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-05) - AP01