-
PI INNOVO LIMITED - Blenheim House, Newmarket Road, Bury St. Edmunds, Suffolk, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07596582
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Blenheim House
- Newmarket Road
- Bury St. Edmunds
- Suffolk
- IP33 3SB Blenheim House, Newmarket Road, Bury St. Edmunds, Suffolk, IP33 3SB UK
Management
- Geschäftsführung
- HUCQ, Brandon Jay
- KIRK, Andrew John
- LUCKING, Walter Gregory
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.04.2011
- Alter der Firma 2011-04-07 13 Jahre
- SIC/NACE
- 71129
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- FRIARS 2033 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-09-30
- Letzte Einreichung: 2013-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-04-21
- Letzte Einreichung:
-
PI INNOVO LIMITED Firmenbeschreibung
- PI INNOVO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07596582. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.04.2011 registriert. PI INNOVO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FRIARS 2033 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71129" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/10/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Blenheim House erreicht werden.
Jetzt sichern PI INNOVO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pi Innovo Limited - Blenheim House, Newmarket Road, Bury St. Edmunds, Suffolk, Grossbritannien
- 2011-04-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PI INNOVO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-01-11) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-01-11) - LIQ10
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-10) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-09-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-02-25) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-02-25) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-09-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-09-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-08-31) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2016-02-09) - 2.24B
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-07-18) - 600
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2016-07-13) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2016-06-30) - 2.34B
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-05) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-05) - AR01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2015-07-15) - 2.12B
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-22) - AD01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2015-09-02) - 2.23B
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2015-12-15) - 1.4
-
liquidation-in-administration-proposals (2015-08-13) - 2.17B
keyboard_arrow_right 2014
-
legacy (2014-11-04) - AGREEMENT2
-
legacy (2014-11-10) - PARENT_ACC
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-16) - AR01
-
legacy (2014-11-04) - GUARANTEE2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2014-11-10) - AA
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2014-10-24) - 1.1
keyboard_arrow_right 2013
-
legacy (2013-10-01) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-15) - AA
-
legacy (2013-10-01) - PARENT_ACC
-
legacy (2013-10-01) - GUARANTEE2
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-11-29) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-08-31) - AA
-
legacy (2012-08-29) - MG01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-08-10) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-04) - AR01
-
capital-alter-shares-subdivision (2012-05-02) - SH02
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-14) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-03) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-11-03) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-03) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-11-03) - TM02
-
certificate-change-of-name-company (2011-11-04) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name (2011-11-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-04) - AP01
-
incorporation-company (2011-04-07) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2011-07-13) - TM01