-
PAOLO & DONATO LIMITED - 24 Tarleton Street, Liverpool, L1 1DS, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07574596
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 24 Tarleton Street
- Liverpool
- L1 1DS
- England 24 Tarleton Street, Liverpool, L1 1DS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CILLO, Rocco Donato
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.03.2011
- Alter der Firma 2011-03-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paolo Cillo
- Mr Rocco Donato Cillo
- -
- Mr. Rocco Donato Cillo
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-12
- Letzte Einreichung: 2022-10-29
-
PAOLO & DONATO LIMITED Firmenbeschreibung
- PAOLO & DONATO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07574596. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.03.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 24 Tarleton Street erreicht werden.
Jetzt sichern PAOLO & DONATO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Paolo & Donato Limited - 24 Tarleton Street, Liverpool, L1 1DS, England, Grossbritannien
- 2011-03-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PAOLO & DONATO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-02-28) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-03-10) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-29) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-05) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-05) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-05) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-05) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-31) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-09-19) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-01-28) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-11) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-06) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-12-05) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-28) - AR01
-
incorporation-company (2011-03-23) - NEWINC