-
AO MOBILE LIMITED - Ao Park 5a The Parklands, Lostock, Bolton, BL6 4SD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07570386
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ao Park 5a The Parklands
- Lostock
- Bolton
- BL6 4SD
- England Ao Park 5a The Parklands, Lostock, Bolton, BL6 4SD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- EMMETT, Daniel Anthony
- HIGGINS, Jonathan Mark Stephen
- ROBERTS, John Charles
- Prokuristen
- FINNEMORE, Julie Angela Louise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.03.2011
- Alter der Firma 2011-03-18 13 Jahre
- SIC/NACE
- 47421
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Susan Jane Borges
- Ao Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MOBILE PHONES DIRECT LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800R3O4HE52J6H421
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-03-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-01
- Letzte Einreichung: 2021-03-18
-
AO MOBILE LIMITED Firmenbeschreibung
- AO MOBILE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07570386. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.03.2011 registriert. AO MOBILE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MOBILE PHONES DIRECT LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47421" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.03.2014.Die Firma kann schriftlich über Ao Park 5A The Parklands erreicht werden.
Jetzt sichern AO MOBILE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ao Mobile Limited - Ao Park 5a The Parklands, Lostock, Bolton, BL6 4SD, Grossbritannien
- 2011-03-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AO MOBILE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-01) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-09-16) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-04-15) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-24) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-12-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-08) - AP01
-
resolution (2019-04-03) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2019-04-03) - CONNOT
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-19) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-14) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-27) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-09-20) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-20) - PSC01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-21) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-12-13) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-12-17) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-12-17) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-17) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-17) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-18) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-18) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-21) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-12-21) - AA
-
change-of-name-notice (2017-03-24) - CONNOT
-
resolution (2017-03-24) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-11-21) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-01-09) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-07) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-10-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-25) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2013-03-26) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-03-27) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-03-20) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-08) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-07-04) - AA
-
legacy (2013-03-28) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-06-10) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-05) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-04-05) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-04) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-04-04) - TM02
-
certificate-change-of-name-company (2011-03-29) - CERTNM
-
incorporation-company (2011-03-18) - NEWINC