-
CRESTEL PROJECTS LTD - Croft Chambers, 11 Bancroft, Hitchin, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07569004
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Croft Chambers
- 11 Bancroft
- Hitchin
- Hertfordshire
- SG5 1JQ Croft Chambers, 11 Bancroft, Hitchin, Hertfordshire, SG5 1JQ UK
Management
- Geschäftsführung
- FITZJOHN, Mick
- FITZJOHN, Simon David
- HALDRON, Laurence Frederick Charles
- LAVERS, Howard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.03.2011
- Alter der Firma 2011-03-17 13 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Howard Lavers
- Mr Simon David Fitzjohn
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-26
- Letzte Einreichung: 2021-01-12
-
CRESTEL PROJECTS LTD Firmenbeschreibung
- CRESTEL PROJECTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07569004. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.03.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Croft Chambers erreicht werden.
Jetzt sichern CRESTEL PROJECTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Crestel Projects Ltd - Croft Chambers, 11 Bancroft, Hitchin, Hertfordshire, Grossbritannien
- 2011-03-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CRESTEL PROJECTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-20) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-11-23) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-16) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-11) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-12) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-12) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-13) - AAMD
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-13) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-08) - AR01
-
capital-allotment-shares (2016-01-27) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-08) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-02) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-20) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-22) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-02) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-09-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-11-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-05) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-04-05) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-03-17) - NEWINC