-
ADAPTIVE FERTILITY SYSTEMS LIMITED - Riverside House Kings Reach Business Park, Yew Street, Stockport, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07557741
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Riverside House Kings Reach Business Park
- Yew Street
- Stockport
- Cheshire
- SK4 2HD Riverside House Kings Reach Business Park, Yew Street, Stockport, Cheshire, SK4 2HD UK
Management
- Geschäftsführung
- MURRAY, Brendan, Dr
- SMITH, Dennis
- ORODJE, Graham
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.03.2011
- Gelöscht am:
- 2021-08-03
- SIC/NACE
- 86900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Brendan Murray
- Mr Brendan Murray
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-22
- Letzte Einreichung: 2021-03-08
-
ADAPTIVE FERTILITY SYSTEMS LIMITED Firmenbeschreibung
- ADAPTIVE FERTILITY SYSTEMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07557741. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 09.03.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Riverside House Kings Reach Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern ADAPTIVE FERTILITY SYSTEMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Adaptive Fertility Systems Limited - Riverside House Kings Reach Business Park, Yew Street, Stockport, Cheshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ADAPTIVE FERTILITY SYSTEMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-03) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-10) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-05-11) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-05-18) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-06-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-05-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-10) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-12-27) - AA01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-06-25) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2016-06-07) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
gazette-notice-compulsory (2015-04-14) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-27) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-05-13) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-04) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-18) - AP01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-05-17) - DISS40
-
capital-allotment-shares (2014-05-29) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-15) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-08) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-11) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-06-08) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-06) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2013-03-12) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-05-25) - SH01
-
resolution (2012-05-25) - RESOLUTIONS
-
resolution (2012-06-18) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name (2012-12-20) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-07-05) - SH01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2012-07-25) - RP04
-
capital-allotment-shares (2012-06-20) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-13) - AP01
-
incorporation-company (2011-03-09) - NEWINC