-
JAFLAS - DR ALAN BLACKER, 4 Margaret Clitherow Court, Milk Street, Rochdale, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07539893
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- DR ALAN BLACKER
- 4 Margaret Clitherow Court
- Milk Street
- Rochdale
- OL11 1HF
- England DR ALAN BLACKER, 4 Margaret Clitherow Court, Milk Street, Rochdale, OL11 1HF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ASHFORTH, Julie Anne
- BLACKER, Alan, Dr The Rt Hon
- BOHILL, Paul John
- SMITH, Glenn
- ASHFORTH, Stephen
- Prokuristen
- BLACKER, Alan, Dr
- THE LORD HARLEY, Alan Blacker, Dr The Rt Hon
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc-limited-exemption
- Gründungsdatum
- 23.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 69109
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dr Alan Blacker
- -
- Dr The Rt Hon Alan Blacker Earl Of Dublin
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-11-30
- Letzte Einreichung: 2020-02-29
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-06
- Letzte Einreichung: 2020-02-23
-
JAFLAS Firmenbeschreibung
- JAFLAS ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc-limited-exemption registrierte Firma mit der Register-Nr. 07539893. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.02.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69109" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 2 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Dr Alan Blacker erreicht werden.
Jetzt sichern JAFLAS HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jaflas - DR ALAN BLACKER, 4 Margaret Clitherow Court, Milk Street, Rochdale, Grossbritannien
- 2011-02-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JAFLAS aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-09-16) - PSC07
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-05-26) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-26) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-31) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-24) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-12) - PSC01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2020-05-27) - CH03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-09-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-11-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-05) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-11-06) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-18) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-23) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-07) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-04) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2016-02-24) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2015-02-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2014-03-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-12) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-19) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-25) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-21) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-03-20) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2013-03-13) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-09-21) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2012-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-02-23) - NEWINC