-
BERRYS GLOBAL INNOVATIONS LIMITED - 141 Lichfield Road, Aston, Birmingham, B6 5SP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07539436
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 141 Lichfield Road
- Aston
- Birmingham
- B6 5SP 141 Lichfield Road, Aston, Birmingham, B6 5SP UK
Management
- Geschäftsführung
- BERRY, Martin Gerard
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-22 13 Jahre
- SIC/NACE
- 26511
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Martin Gerard Berry
- Dr Jacque Williams
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- FLUID ID SYSTEMS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-07
- Letzte Einreichung: 2023-02-22
-
BERRYS GLOBAL INNOVATIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- BERRYS GLOBAL INNOVATIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07539436. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.02.2011 registriert. BERRYS GLOBAL INNOVATIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FLUID ID SYSTEMS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "26511" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 29/02/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 141 Lichfield Road erreicht werden.
Jetzt sichern BERRYS GLOBAL INNOVATIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Berrys Global Innovations Limited - 141 Lichfield Road, Aston, Birmingham, B6 5SP, Grossbritannien
- 2011-02-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BERRYS GLOBAL INNOVATIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-08-04) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-08-04) - TM02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-08-04) - PSC04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-08-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-08-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-07) - CS01
-
resolution (2019-02-04) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2019-01-30) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-08-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-09-05) - AA
-
resolution (2017-05-18) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2017-05-22) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-05-24) - SH08
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-10) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-03-11) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-13) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-28) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-08-12) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-27) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-14) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-17) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-26) - AR01
-
move-registers-to-sail-company (2012-03-21) - AD03
-
change-sail-address-company-with-old-address (2012-03-21) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-03-21) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-sail-address-company (2011-03-25) - AD02
-
incorporation-company (2011-02-22) - NEWINC