-
RUGBY FARMERS MART LIMITED - The Charolais Pavilion Avenue M, Stoneleigh Park, Kenilworth, Warwickshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07536208
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Charolais Pavilion Avenue M
- Stoneleigh Park
- Kenilworth
- Warwickshire
- CV8 2RG
- England The Charolais Pavilion Avenue M, Stoneleigh Park, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2RG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ELLIS, Richard Thomas George
- HECKFORD, Richard John
- HULL, Edward Andrew
- SMITH, Lynda Mary Kirk
- THOMAS, Cecil Watson
- WOODWARD, Martin James
- Prokuristen
- ELLIS, Richard Thomas George
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-21 13 Jahre
- SIC/NACE
- 46110
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- R.F.M (WARWICKSHIRE) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-04
- Letzte Einreichung: 2020-02-21
-
RUGBY FARMERS MART LIMITED Firmenbeschreibung
- RUGBY FARMERS MART LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07536208. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.02.2011 registriert. RUGBY FARMERS MART LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen R.F.M (WARWICKSHIRE) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46110" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Charolais Pavilion Avenue M erreicht werden.
Jetzt sichern RUGBY FARMERS MART LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rugby Farmers Mart Limited - The Charolais Pavilion Avenue M, Stoneleigh Park, Kenilworth, Warwickshire, Grossbritannien
- 2011-02-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RUGBY FARMERS MART LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-23) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-16) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-01-16) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-23) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-28) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-28) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-17) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-04) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-02-12) - SH01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-03-25) - CH01
-
capital-allotment-shares (2011-04-26) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2011-04-26) - SH08
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-04-26) - AA01
-
incorporation-company (2011-02-21) - NEWINC
-
change-of-name-notice (2011-03-23) - CONNOT
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-03) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2011-03-31) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-06) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-09) - AP01
-
legacy (2011-05-17) - MG01
-
resolution (2011-04-26) - RESOLUTIONS