-
EVALA LIMITED - 23 Spring Street, London, W2 1JA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07536147
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 23 Spring Street
- London
- W2 1JA 23 Spring Street, London, W2 1JA UK
Management
- Geschäftsführung
- GOURGEY, Charles Richard
- YOUNG, Craig Robert
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-21 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Joshua Properties Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-14
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
-
EVALA LIMITED Firmenbeschreibung
- EVALA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07536147. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.02.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.02.2013.Die Firma kann schriftlich über 23 Spring Street erreicht werden.
Jetzt sichern EVALA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Evala Limited - 23 Spring Street, London, W2 1JA, Grossbritannien
- 2011-02-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EVALA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-26) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-07-04) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-07-03) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-13) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-07-08) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2016-07-05) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-25) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-01-21) - MR04
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-07-09) - DISS40
keyboard_arrow_right 2015
-
auditors-resignation-company (2015-11-23) - AUD
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-05-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-16) - AR01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2015-02-18) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2015-02-18) - AD02
keyboard_arrow_right 2014
-
auditors-resignation-company (2014-09-26) - AUD
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-04-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
memorandum-articles (2013-07-22) - MEM/ARTS
-
resolution (2013-07-22) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-07-13) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-28) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-05-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-23) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-01-31) - AA01
-
miscellaneous (2012-10-08) - MISC
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-03) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-10-06) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-12) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-03) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-03) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-02-25) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2011-02-25) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-25) - AD01
-
incorporation-company (2011-02-21) - NEWINC