-
DAVIES STREET CASTLE CITY LIMITED - The Old Workshop, 1 Ecclesall Road South, Sheffield, S11 9PA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07532198
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Old Workshop
- 1 Ecclesall Road South
- Sheffield
- S11 9PA The Old Workshop, 1 Ecclesall Road South, Sheffield, S11 9PA UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- JARVIS, Alison Kay
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-16 13 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Barry Henderson
- Mr Edward Harry John Davies
- Mr Steven Nicholas Burton
- Mr Barry Henderson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-11-30
- Letzte Einreichung: 2020-02-29
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-30
- Letzte Einreichung: 2020-02-16
-
DAVIES STREET CASTLE CITY LIMITED Firmenbeschreibung
- DAVIES STREET CASTLE CITY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07532198. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.02.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.02.2013.Die Firma kann schriftlich über The Old Workshop erreicht werden.
Jetzt sichern DAVIES STREET CASTLE CITY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Davies Street Castle City Limited - The Old Workshop, 1 Ecclesall Road South, Sheffield, S11 9PA, Grossbritannien
- 2011-02-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DAVIES STREET CASTLE CITY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-03-12) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-03-23) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-19) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-09) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-06) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-03-01) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-01) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-06) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-06) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-12-07) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-29) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-18) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-09-04) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-03-15) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2012-03-20) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-09) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-02-16) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-11) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-06-13) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2011-06-13) - TM01
-
appoint-corporate-director-company-with-name (2011-06-13) - AP02
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-19) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-05-11) - AP03