-
SOUTH TOTTENHAM KEHILA LIMITED - 3rd Floor, Solar House, 1-9 Romford Road, London, E15 4RG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07522813
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd Floor, Solar House
- 1-9 Romford Road
- London
- E15 4RG
- United Kingdom 3rd Floor, Solar House, 1-9 Romford Road, London, E15 4RG, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BIBERFELD, Chaim Michael
- FRIEDMAN, Dov Bernard
- POVARSKI, Binyamin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-09 13 Jahre
- SIC/NACE
- 94910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael Biberfeld
- Mr Michael Biberfeld
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- JALAN LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-04-27
- Letzte Einreichung: 2018-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-23
- Letzte Einreichung: 2020-02-09
-
SOUTH TOTTENHAM KEHILA LIMITED Firmenbeschreibung
- SOUTH TOTTENHAM KEHILA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07522813. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.02.2011 registriert. SOUTH TOTTENHAM KEHILA LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen JALAN LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "94910" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28.02.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3Rd Floor, Solar House erreicht werden.
Jetzt sichern SOUTH TOTTENHAM KEHILA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: South Tottenham Kehila Limited - 3rd Floor, Solar House, 1-9 Romford Road, London, E15 4RG, Grossbritannien
- 2011-02-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOUTH TOTTENHAM KEHILA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-01-26) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-19) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-21) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-01-27) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-10-30) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-12) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-02-08) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2018-01-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-01-30) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-19) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-07-03) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-19) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-07-21) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-06) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2017-09-09) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2017-08-08) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-11-30) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-01) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-03-05) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2014-03-04) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-09-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-03-30) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2011-03-30) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-30) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-07-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-25) - AP01
-
incorporation-company (2011-02-09) - NEWINC
-
resolution (2011-11-28) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name (2011-07-14) - TM01