-
SABE INTERACTIVE LTD - Bedford Ilab Stannard Way, Priory Business Park, Bedford, MK44 3RZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07516640
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bedford Ilab Stannard Way
- Priory Business Park
- Bedford
- MK44 3RZ Bedford Ilab Stannard Way, Priory Business Park, Bedford, MK44 3RZ UK
Management
- Geschäftsführung
- FURR, Samuel Charles
- SINGH, Rajpal
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-03 13 Jahre
- SIC/NACE
- 58210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Samuel Charles Furr
- -
- Kimiti Consulting Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-11-30
- Letzte Einreichung: 2023-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-24
- Letzte Einreichung: 2023-12-10
-
SABE INTERACTIVE LTD Firmenbeschreibung
- SABE INTERACTIVE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07516640. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.02.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58210" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28.02.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Bedford Ilab Stannard Way erreicht werden.
Jetzt sichern SABE INTERACTIVE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sabe Interactive Ltd - Bedford Ilab Stannard Way, Priory Business Park, Bedford, MK44 3RZ, Grossbritannien
- 2011-02-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SABE INTERACTIVE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
capital-cancellation-shares (2024-01-16) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2024-01-16) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2024-01-15) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2024-01-15) - SH03
keyboard_arrow_right 2023
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-12-19) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-12-12) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-12-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-05-18) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-12-16) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-12-16) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-01) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-06-16) - PSC04
-
capital-allotment-shares (2022-06-15) - SH01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-12-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-20) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-10) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-13) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-15) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-17) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-04) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-10-22) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-11) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-12-10) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-23) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-02) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-26) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-02-03) - NEWINC