-
VMS MANCHESTER LIMITED - Ground Floor, 31 Kentish Town Road, London, NW1 8NL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07506626
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ground Floor
- 31 Kentish Town Road
- London
- NW1 8NL
- England Ground Floor, 31 Kentish Town Road, London, NW1 8NL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FORSTER, Catherine Siobhan
- VAN HORCK, Bert Victor
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.01.2011
- Gelöscht am:
- 2021-10-26
- SIC/NACE
- 90040
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr. Stephen Forster
- Mr Stephen Forster
- Mrs Catherine Siobhan Forster
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- BIRMINGHAM BALLROOM LIVE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-09
- Letzte Einreichung: 2020-01-26
-
VMS MANCHESTER LIMITED Firmenbeschreibung
- VMS MANCHESTER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07506626. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 26.01.2011 registriert. VMS MANCHESTER LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BIRMINGHAM BALLROOM LIVE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "90040" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 26/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Ground Floor erreicht werden.
Jetzt sichern VMS MANCHESTER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vms Manchester Limited - Ground Floor, 31 Kentish Town Road, London, NW1 8NL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VMS MANCHESTER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-28) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-27) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-02-27) - TM02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-27) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-27) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-27) - PSC01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-10) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-16) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-02-28) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-24) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-11-25) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2013-03-21) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-03-21) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-10-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-06-29) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-06-29) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-29) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-06-29) - AD01
-
change-of-name-notice (2011-07-15) - CONNOT
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-07-19) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-07-19) - TM01
-
resolution (2011-07-19) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2011-07-15) - CERTNM
-
incorporation-company (2011-01-26) - NEWINC