-
BHP IT LIMITED - 3rd Floor Westfield House, 60 Charter Row, Sheffield, S1 3FZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07504925
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd Floor Westfield House
- 60 Charter Row
- Sheffield
- S1 3FZ 3rd Floor Westfield House, 60 Charter Row, Sheffield, S1 3FZ UK
Management
- Geschäftsführung
- MR ANDREW JAMES BARKER
- MR MICHAEL GEOFFREY BARKER
- MR ANTHONY WALKER
- BARKER, Andrew James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-25 13 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew James Barker
- Mr Anthony Walker
- Mrs Kirstie Barker
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- WAKECO (427) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-01-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-02-08
- Letzte Einreichung: 2022-01-25
-
BHP IT LIMITED Firmenbeschreibung
- BHP IT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07504925. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.01.2011 registriert. BHP IT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WAKECO (427) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.01.2012.Die Firma kann schriftlich über 3Rd Floor Westfield House erreicht werden.
Jetzt sichern BHP IT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bhp It Limited - 3rd Floor Westfield House, 60 Charter Row, Sheffield, S1 3FZ, Grossbritannien
- 2011-01-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BHP IT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2024-04-14) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-05-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
resolution (2022-04-07) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2022-04-07) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-04-06) - 600
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-26) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-04-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-16) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-09-27) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-03) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-03) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-07) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-05-30) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-05-22) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-21) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2013-05-21) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-03-08) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-09) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-07-26) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-11) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
certificate-change-of-name-company (2011-05-23) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-05-23) - CONNOT
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-04-26) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-26) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-26) - AP01
-
incorporation-company (2011-01-25) - NEWINC