-
NITRAFLOW PROPERTIES & HANDLING LIMITED - Floor 3, Ferry House, South Denes Road, Great Yarmouth, Norfolk, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07504822
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Floor 3, Ferry House
- South Denes Road
- Great Yarmouth
- Norfolk
- NR30 3PJ
- England Floor 3, Ferry House, South Denes Road, Great Yarmouth, Norfolk, NR30 3PJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FULLER, John Charles
- FULLER, Michael John
- THORPE, Stephen Charles
- VINCENT, Keith Richard
- Prokuristen
- VINCENT, Keith Richard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-25 13 Jahre
- SIC/NACE
- 20150
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-08
- Letzte Einreichung: 2021-01-25
-
NITRAFLOW PROPERTIES & HANDLING LIMITED Firmenbeschreibung
- NITRAFLOW PROPERTIES & HANDLING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07504822. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "20150" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Floor 3, Ferry House erreicht werden.
Jetzt sichern NITRAFLOW PROPERTIES & HANDLING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nitraflow Properties & Handling Limited - Floor 3, Ferry House, South Denes Road, Great Yarmouth, Norfolk, Grossbritannien
- 2011-01-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NITRAFLOW PROPERTIES & HANDLING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-06) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-04) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-20) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-16) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-17) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-07) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-23) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2014-02-14) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-10) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-09) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-18) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-04) - AP01
-
resolution (2011-03-07) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2011-03-11) - SH01
-
incorporation-company (2011-01-25) - NEWINC
-
legacy (2011-03-30) - MG01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-18) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-18) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-11-01) - AA01
-
capital-alter-shares-subdivision (2011-03-07) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-14) - AP01