-
HILTON BODILL (CONSTRUCTION) LIMITED - Fao K2 Management Solutions Ltd Toll Bar House, 1 Derby Road, Ilkeston, Derbyshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07504575
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Fao K2 Management Solutions Ltd Toll Bar House
- 1 Derby Road
- Ilkeston
- Derbyshire
- DE7 5FH
- England Fao K2 Management Solutions Ltd Toll Bar House, 1 Derby Road, Ilkeston, Derbyshire, DE7 5FH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ELLINGTON, Kym Christopher
- GORENSWEIGH, John Nicholas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-25 13 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kym Christopher Ellington
- Mr John Nicholas Gorensweigh
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-10-31
- Letzte Einreichung: 2022-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-16
- Letzte Einreichung: 2023-02-02
-
HILTON BODILL (CONSTRUCTION) LIMITED Firmenbeschreibung
- HILTON BODILL (CONSTRUCTION) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07504575. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Fao K2 Management Solutions Ltd Toll Bar House erreicht werden.
Jetzt sichern HILTON BODILL (CONSTRUCTION) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hilton Bodill (Construction) Limited - Fao K2 Management Solutions Ltd Toll Bar House, 1 Derby Road, Ilkeston, Derbyshire, Grossbritannien
- 2011-01-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HILTON BODILL (CONSTRUCTION) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-03) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-09-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-10-18) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-10-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-07-27) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-21) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-05) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-04) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-22) - AD01
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-08-12) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-19) - AA
-
capital-cancellation-shares (2015-08-12) - SH06
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-return-purchase-own-shares (2014-08-06) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2014-08-06) - SH06
-
resolution (2014-08-06) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-17) - AA
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2013-07-09) - RP04
-
resolution (2013-07-16) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2013-07-16) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2013-07-16) - SH06
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-10) - AR01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2012-01-13) - SH10
-
resolution (2012-01-13) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-01-25) - NEWINC
-
legacy (2011-06-18) - MG01