-
SHAKEAWAY WORLDWIDE LIMITED - 8 St. Stephens Court, 15-17 St. Stephens Road, Bournemouth, Dorset, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07500524
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 St. Stephens Court
- 15-17 St. Stephens Road
- Bournemouth
- Dorset
- BH2 6LA 8 St. Stephens Court, 15-17 St. Stephens Road, Bournemouth, Dorset, BH2 6LA UK
Management
- Geschäftsführung
- CLACK, Andrew Denis
- DICKSON, Peter John
- IBZEA, Ahmed
- IBZEA, Mohammed
- TUCK, Carole
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-21 13 Jahre
- SIC/NACE
- 47250
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Shakeaway Worldwide Holdings Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SPN ACQUISITIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-10-31
- Letzte Einreichung: 2021-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-02-04
- Letzte Einreichung: 2022-01-21
-
SHAKEAWAY WORLDWIDE LIMITED Firmenbeschreibung
- SHAKEAWAY WORLDWIDE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07500524. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.01.2011 registriert. SHAKEAWAY WORLDWIDE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SPN ACQUISITIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47250" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.01.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 8 St. Stephens Court erreicht werden.
Jetzt sichern SHAKEAWAY WORLDWIDE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Shakeaway Worldwide Limited - 8 St. Stephens Court, 15-17 St. Stephens Road, Bournemouth, Dorset, Grossbritannien
- 2011-01-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SHAKEAWAY WORLDWIDE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-06-14) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-25) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-05-19) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-27) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-06-07) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-03-30) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-08-11) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-28) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-26) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-26) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2017-07-26) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-26) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-07-26) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-16) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-18) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-10) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-02-16) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-04-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-07-22) - MG01
-
resolution (2011-04-12) - RESOLUTIONS
-
legacy (2011-03-25) - MG01
-
certificate-change-of-name-company (2011-03-17) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-03-17) - CONNOT
-
legacy (2011-02-16) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-04) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-04) - AD01
-
incorporation-company (2011-01-21) - NEWINC