-
G M WILSON SOLICITORS LIMITED - 1 Crown Court, Wakefield, WF1 2SU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07496676
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Crown Court
- Wakefield
- WF1 2SU 1 Crown Court, Wakefield, WF1 2SU UK
Management
- Geschäftsführung
- BROOKE, David Richard
- HOLMES, Corrie
- KIRKHAM, Rachel
- MARRIS, James Peter
- WASHINGTON, Nicola Kay
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-18 13 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr James Peter Marris
- Mrs Corrie Holmes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-10-31
- Letzte Einreichung: 2019-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-01
- Letzte Einreichung: 2020-01-18
-
G M WILSON SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- G M WILSON SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07496676. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 1 Crown Court erreicht werden.
Jetzt sichern G M WILSON SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: G M Wilson Solicitors Limited - 1 Crown Court, Wakefield, WF1 2SU, Grossbritannien
- 2011-01-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu G M WILSON SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-08) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-28) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-10) - AP01
-
capital-allotment-shares (2020-03-24) - SH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-03-21) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-21) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-21) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-16) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-02) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-24) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-10-17) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-08) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-08) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-17) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-11) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-03) - AR01
-
move-registers-to-registered-office-company-with-new-address (2015-02-03) - AD04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-11) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-05-12) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-03) - AR01
-
change-sail-address-company-with-old-address (2014-02-03) - AD02
keyboard_arrow_right 2013
-
change-sail-address-company (2013-02-01) - AD02
-
move-registers-to-sail-company (2013-02-04) - AD03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-04-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-01-18) - NEWINC