-
DIRECT REDRESS LIMITED - Booths Park 5, Chelford Road, Knutsford, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07489855
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Booths Park 5
- Chelford Road
- Knutsford
- Cheshire
- WA16 8GS Booths Park 5, Chelford Road, Knutsford, Cheshire, WA16 8GS UK
Management
- Geschäftsführung
- LEWIS, Daniel
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-12 13 Jahre
- SIC/NACE
- 66190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Daniel Christopher Lewis
- Dl Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-28
- Letzte Einreichung: 2023-06-14
-
DIRECT REDRESS LIMITED Firmenbeschreibung
- DIRECT REDRESS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07489855. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66190" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Booths Park 5 erreicht werden.
Jetzt sichern DIRECT REDRESS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Direct Redress Limited - Booths Park 5, Chelford Road, Knutsford, Cheshire, Grossbritannien
- 2011-01-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DIRECT REDRESS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-16) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-18) - PSC05
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-09) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-11) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-20) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-19) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-15) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-23) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-25) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-04) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-12) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2013-03-28) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-08) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-02-08) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2013-02-08) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-11) - AA
-
capital-allotment-shares (2012-02-03) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-01-12) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-10-12) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-08) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2011-05-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-16) - AP01