-
VISION OFFICE AUTOMATION LONDON LIMITED - Caxton House Watermark Way, Foxholes Business Park, Hertford, SG13 7TZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07489767
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Caxton House Watermark Way
- Foxholes Business Park
- Hertford
- SG13 7TZ Caxton House Watermark Way, Foxholes Business Park, Hertford, SG13 7TZ UK
Management
- Geschäftsführung
- BOND, Allen
- BOND, Philip Roy
- ROBINSON, Earl
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.01.2011
- Gelöscht am:
- 2022-01-04
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Allen Bond
- Mr Philip Bond
- Mr Earl Robinson
- -
- -
- -
- Visiontel Europe Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-26
- Letzte Einreichung: 2021-01-12
-
VISION OFFICE AUTOMATION LONDON LIMITED Firmenbeschreibung
- VISION OFFICE AUTOMATION LONDON LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07489767. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 12.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Caxton House Watermark Way erreicht werden.
Jetzt sichern VISION OFFICE AUTOMATION LONDON LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vision Office Automation London Limited - Caxton House Watermark Way, Foxholes Business Park, Hertford, SG13 7TZ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VISION OFFICE AUTOMATION LONDON LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-08-17) - SOAS(A)
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-07-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-15) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-06-15) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-06-22) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-07-07) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-01) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-01) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-07-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-07-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-05-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-27) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-04-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-19) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-11) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-22) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-05) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-06) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-02-05) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-02-05) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2014-05-12) - TM02
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-07-23) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-04-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-07-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-17) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2012-07-12) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-07-12) - TM02
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-09-02) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-02) - AD01
-
incorporation-company (2011-01-12) - NEWINC