-
NEWLANDS COFFEE LIMITED - Unit 9 Easter Court, Europa Boulevard, Westbrook, Warrington, WA5 7ZB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07476611
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 9 Easter Court, Europa Boulevard
- Westbrook
- Warrington
- WA5 7ZB
- England Unit 9 Easter Court, Europa Boulevard, Westbrook, Warrington, WA5 7ZB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GARRIHY, Donal
- SMYTH, Peter
- Prokuristen
- SMYTH, Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-22 13 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Pete Smyth
- Mr Donal Garrihy
- Mr Pete Smyth
- Mr Donal Garrihy
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-05
- Letzte Einreichung: 2020-12-22
-
NEWLANDS COFFEE LIMITED Firmenbeschreibung
- NEWLANDS COFFEE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07476611. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 9 Easter Court, Europa Boulevard erreicht werden.
Jetzt sichern NEWLANDS COFFEE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Newlands Coffee Limited - Unit 9 Easter Court, Europa Boulevard, Westbrook, Warrington, WA5 7ZB, Grossbritannien
- 2010-12-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEWLANDS COFFEE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
legacy (2021-09-15) - SH20
-
gazette-notice-compulsory (2021-04-06) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-04-17) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-29) - AA
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-09-15) - SH19
-
legacy (2021-09-15) - CAP-SS
-
resolution (2021-09-15) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-01-22) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-01-04) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-02) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-11-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-12-11) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-12) - DISS40
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-01) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-01) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-10-23) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-14) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-10-14) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-10-14) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-14) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-02) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-11-13) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-05) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-08-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-08-08) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-01-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-21) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-02-21) - SH01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-22) - NEWINC