-
ORICO (LONDON) LIMITED - Bryant House Bryant Road, Strood, Rochester, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07475404
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bryant House Bryant Road
- Strood
- Rochester
- Kent
- ME2 3EW Bryant House Bryant Road, Strood, Rochester, Kent, ME2 3EW UK
Management
- Geschäftsführung
- ABELA, Albert John Martin
- CHAOULI, Chapour Ezra
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.12.2010
- Gelöscht am:
- 2020-11-03
- SIC/NACE
- 47750
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Chapour Ezra Chaouli
- Mr Albert John Martin Abela
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- TRUE ORGANIC BRANDS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2018-12-29
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-21
-
ORICO (LONDON) LIMITED Firmenbeschreibung
- ORICO (LONDON) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07475404. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.12.2010 registriert. ORICO (LONDON) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TRUE ORGANIC BRANDS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47750" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Bryant House Bryant Road erreicht werden.
Jetzt sichern ORICO (LONDON) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Orico (London) Limited - Bryant House Bryant Road, Strood, Rochester, Kent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ORICO (LONDON) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-11-03) - GAZ2
-
gazette-notice-compulsory (2020-03-10) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-01-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-28) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-02-15) - AA
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2018-01-12) - DS02
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-notice-compulsory (2017-03-21) - GAZ1
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-04-10) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-04-11) - DISS40
-
dissolution-application-strike-off-company (2017-11-02) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2017-11-14) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-03-23) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-22) - CH01
-
gazette-notice-compulsory (2016-03-15) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-10-01) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-21) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-09-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
statement-of-companys-objects (2013-12-04) - CC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-25) - AA
-
legacy (2013-01-22) - MG01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-01-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-01-20) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-20) - AR01
-
change-of-name-notice (2012-02-10) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2012-02-10) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-02) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-22) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-08-15) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-15) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-06-30) - AD01
-
resolution (2011-05-19) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-01-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-21) - NEWINC