-
DEVELOPMENT DELIVERY INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED - 4 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 1EE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07472347
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Mount Ephraim Road
- Tunbridge Wells
- Kent
- TN1 1EE 4 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 1EE UK
Management
- Geschäftsführung
- SMITH, Carole Ann
- SMITH, Richard Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.12.2010
- Gelöscht am:
- 2020-11-15
- SIC/NACE
- 70229
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- DEVELOPMENT DELIVERY INTERNATIONAL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2015-07-26
-
DEVELOPMENT DELIVERY INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED Firmenbeschreibung
- DEVELOPMENT DELIVERY INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07472347. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.12.2010 registriert. DEVELOPMENT DELIVERY INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DEVELOPMENT DELIVERY INTERNATIONAL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4 Mount Ephraim Road erreicht werden.
Jetzt sichern DEVELOPMENT DELIVERY INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Development Delivery International (Holdings) Limited - 4 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 1EE, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DEVELOPMENT DELIVERY INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-11-15) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-08-15) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-09-26) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-09-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-09-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-09-28) - 4.68
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-11) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2015-08-10) - 4.70
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-08-10) - 600
-
resolution (2015-08-10) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-24) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-17) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-15) - AA
-
legacy (2013-01-17) - MG02
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2012-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-12-28) - CH01
-
certificate-change-of-name-company (2011-03-31) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-03-31) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-18) - AD01
-
capital-allotment-shares (2011-03-18) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-03-18) - AA01
-
legacy (2011-02-01) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-16) - NEWINC