-
AUTOTECH RECRUIT LIMITED - Libra Building Sunrise Parkway, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07463246
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Libra Building Sunrise Parkway
- Linford Wood
- Milton Keynes
- MK14 6PH
- England Libra Building Sunrise Parkway, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HUGHES, Stephen Iain
- SLY, Andrew James
- Prokuristen
- HUNTER, Dominic Edward
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-08 13 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Stephen Iain Hughes
- Mr Andrew James Sly
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-12
- Letzte Einreichung: 2023-09-28
-
AUTOTECH RECRUIT LIMITED Firmenbeschreibung
- AUTOTECH RECRUIT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07463246. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Libra Building Sunrise Parkway erreicht werden.
Jetzt sichern AUTOTECH RECRUIT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Autotech Recruit Limited - Libra Building Sunrise Parkway, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PH, Grossbritannien
- 2010-12-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AUTOTECH RECRUIT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
capital-alter-shares-subdivision (2024-02-20) - SH02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-02-19) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-02-19) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-02-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-15) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-09-26) - AP03
-
confirmation-statement-with-updates (2023-09-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-22) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-12-21) - MR04
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-20) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-13) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-11) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-22) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-13) - CS01
-
resolution (2016-05-16) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-05-13) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-21) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-02-08) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-12-12) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-01-11) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-16) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-07) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-04-07) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-12-31) - TM01
-
incorporation-company (2010-12-08) - NEWINC