-
REMOVERS & STORERS LIMITED - FORTUS RECOVERY LIMITED, Grove House Meridians Cross Ocean Village, Southampton, SO14 3TJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07461940
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- FORTUS RECOVERY LIMITED
- Grove House Meridians Cross Ocean Village
- Southampton
- SO14 3TJ FORTUS RECOVERY LIMITED, Grove House Meridians Cross Ocean Village, Southampton, SO14 3TJ UK
Management
- Geschäftsführung
- BEDDING, Gillian
- BEDDING, Jason John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-07 13 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jason John Bedding
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-02-28
- Letzte Einreichung: 2015-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-11-14
- Letzte Einreichung: 2018-10-31
-
REMOVERS & STORERS LIMITED Firmenbeschreibung
- REMOVERS & STORERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07461940. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2015 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Fortus Recovery Limited erreicht werden.
Jetzt sichern REMOVERS & STORERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Removers & Storers Limited - FORTUS RECOVERY LIMITED, Grove House Meridians Cross Ocean Village, Southampton, SO14 3TJ, Grossbritannien
- 2010-12-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REMOVERS & STORERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-01) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-02-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-11-23) - LIQ02
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2019-01-08) - LIQ MISC OC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-25) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-22) - PSC01
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2019-08-15) - CVA3
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2019-01-08) - CVA1
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2019-11-06) - CVA4
-
resolution (2019-11-23) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-11-23) - 600
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-31) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-31) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-31) - CS01
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2018-08-18) - CVA3
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2017-06-16) - CVA1
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-08-29) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-30) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-12) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-24) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-19) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-22) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-05-25) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-07) - NEWINC