-
PROBUS SURGERY LIMITED - The Surgery Tregony Road, Probus, Truro, Cornwall, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07450536
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Surgery Tregony Road
- Probus
- Truro
- Cornwall
- TR2 4JZ The Surgery Tregony Road, Probus, Truro, Cornwall, TR2 4JZ UK
Management
- Geschäftsführung
- CASEY, Spencer
- LIN SIN CHO, Gaetan, Dr
- MOON, Grace Elizabeth, Dr
- MURTHY, Rawlins Steve, Dr
- SMITHSON, Kayleigh, Dr
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-24 13 Jahre
- SIC/NACE
- 86210
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-08
- Letzte Einreichung: 2023-11-24
-
PROBUS SURGERY LIMITED Firmenbeschreibung
- PROBUS SURGERY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07450536. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86210" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Surgery Tregony Road erreicht werden.
Jetzt sichern PROBUS SURGERY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Probus Surgery Limited - The Surgery Tregony Road, Probus, Truro, Cornwall, Grossbritannien
- 2010-11-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROBUS SURGERY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-06) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-06-29) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-10-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-10-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-24) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-11-24) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-11-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-06) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-02) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-02-05) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-17) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-11-27) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-15) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-08) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-23) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-12-16) - SH02
-
resolution (2013-12-16) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-02-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-07-27) - AA01
-
capital-allotment-shares (2011-06-08) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2011-02-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-16) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-24) - NEWINC