-
SITEL UK FINANCE - Earlsdon Park, 53-55 Butts Road, Coventry, CV1 3BH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07448789
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Earlsdon Park
- 53-55 Butts Road
- Coventry
- CV1 3BH
- United Kingdom Earlsdon Park, 53-55 Butts Road, Coventry, CV1 3BH, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BROUGH, Karl Vernon
- DE CASTRO, Pedro Lozano
- Prokuristen
- HAYWARD, John William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-unlimited
- Gründungsdatum
- 23.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-04
- Letzte Einreichung: 2019-11-23
-
SITEL UK FINANCE Firmenbeschreibung
- SITEL UK FINANCE ist eine in Grossbritannien als private-unlimited registrierte Firma mit der Register-Nr. 07448789. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Earlsdon Park erreicht werden.
Jetzt sichern SITEL UK FINANCE HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sitel Uk Finance - Earlsdon Park, 53-55 Butts Road, Coventry, CV1 3BH, Grossbritannien
- 2010-11-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SITEL UK FINANCE aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
resolution (2020-10-02) - RESOLUTIONS
-
legacy (2020-01-29) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-01-29) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-10-02) - AA
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-01-29) - AA
-
legacy (2020-10-02) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-10-02) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-10-02) - PARENT_ACC
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-27) - CS01
-
legacy (2019-11-11) - GUARANTEE2
-
legacy (2019-10-03) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-29) - CS01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-11-12) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-13) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-15) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-10) - AA
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2016-06-28) - RP04
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2016-06-17) - RP04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-07) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-10-09) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-08-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-08-16) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-05) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2013-01-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-01-12) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-16) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-07-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-28) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-06-27) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-13) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-12) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-12-12) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2011-11-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-23) - NEWINC